The Kingealogy Family Tree
The Study of Sapps and Kings
His Side
Her Side
Our Blog
Find
Surnames
First Names
Search People
Search Families
Search Site
Places
Dates
Calendar
Cemeteries
Bookmarks
Media
Photos
Documents
Headstones
Histories
Military
DNA
All Media
Info
What's New
Most Wanted
Reports
Statistics
Trees
Branches
Notes
Sources
Repositories
DNA Tests
Contact Us
Home
Search
Login
Your Bookmarks
Share
Print
Bookmark
Note: This site uses cookies.
View policy
I understand
Thomas Budd
Abt 1575 - Abt 1635 (60 years)
Individual
Ancestors
Descendants
Relationship
Timeline
Family
GEDCOM
Suggest
Generations:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Standard
|
Compact
|
Vertical
|
Text
|
Register
|
Tables
|
PDF
(
= Descendancy chart to this point,
= Expand,
= Collapse)
Expand all
|
Collapse all
1
Thomas Budd
[1]
b. Abt 1575 d. Abt 1635
Margaret West
b. Abt 1577 d. Abt 1639
2
John Budd
[1.1]
b. Abt 1597 d. Abt 1657
3
Elizabeth Budd
[1.1.1]
b. Abt 1619 d. Abt 1680
THOMAS BIRD
b. Abt 1618 d. Abt 1678
4
JOHN BIRD
[1.1.1.1]
b. Abt 1640 d. Abt 1700
Grace Stagg
b. Abt 1642 d. Abt 1704
5
THOMAS BIRD
[1.1.1.1.1]
b. Abt 1662 d. Abt 1700
MARY BAUGH
b. Abt 1662 d. Abt 1722
6
BARBARA BIRD
[1.1.1.1.1.1]
b. 1684 d. 1748
Sven Rambo, Sr.
b. 19 Oct 1677 d. 1730
7
Jacob Jackson Rambo
[1.1.1.1.1.1.1]
b. 1727 d. 1803
DEBORAH ALLEN
b. 1727 d. 1790
8
Margaret Rambo
[1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1755 d. 8 Sep 1802
Isaac Barefoot Runyan
b. 06 Jun 1757 d. 1875
9
MARGARET ELIZABETH RUNYON
[1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 19 Aug 1779 d. 6 Aug 1852
NATHANIEL M. KING, Sr.
b. 1770 d. 18 Nov 1843
10
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.1]
b. 1796 d. Bet. 1796 - 1890
10
Lavina King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2]
b. 1796 d. 1875
William M. Clabaugh, Sr.
b. 1782 d. 1858
11
William M. Clabough, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1]
b. 1820 d. 1880
Elizabeth Handley
b. 1824 d. 1900
12
James R. Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.1]
b. 01 Sep 1840 d. 28 Mar 1929 [
=>
]
12
William M. Clabaugh, III
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.2]
b. 8 Nov 1841 d. 28 May 1918 [
=>
]
12
Samuel Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.3]
b. 1845 d. Between 1846 and 1935
12
Mary Jane Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.4]
b. 26 Aug 1846 d. 03 Jan 1917 [
=>
]
12
Charles Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.5]
b. 1849 d. Between 1883 - 1940 [
=>
]
12
Henry Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.6]
b. 28 Nov 1850 d. 21 Feb 1930 [
=>
]
12
_____ Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.7]
b. 1854 d. Bet. 1854 - 1948
12
Aaron Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.8]
b. 1856 d. 1921 [
=>
]
12
Elijah Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.9]
b. Aug 1856 d. 26 Mar 1936 [
=>
]
12
Nancy Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.10]
b. 1860 d. Between 1860 and 1954
12
Archibald Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.1.11]
b. 08 Aug 1862 d. 10 May 1938 [
=>
]
11
James R. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2]
b. 1822 d. 1900
Sarah Dickson
b. 1823 d. Feb 1859
12
Mary Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.1]
b. 1840 d. Between 1841 and 1934
12
John Alexander Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.2]
b. Jan 1842 d. Bet. 1874 - 1934 [
=>
]
12
Archibold A. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.3]
b. 1845 d. Between 1890 and 1910 [
=>
]
12
Martin Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.4]
b. 1847 d. Between 1848 and 1937
12
Elizabeth Jane Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.5]
b. 1849 d. Between 1849 and 1944
12
Henry Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.6]
b. Dec 1851 d. 1924 [
=>
]
12
_____ Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.7]
b. Abt 1853 d. Bet. 1853 - 1900
12
_____ Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.8]
b. Abt 1855 d. Bet. 1855 - 1900
12
William J. Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.9]
b. Oct 1856 d. Bet. 1898 - 1947 [
=>
]
12
Nancy Jane Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.10]
b. 1859 d. Between 1859 and 1953
Nancy Adeline King
b. Dec 1839 d. 1900
12
_____ Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.11]
b. 1861 d. Bet. 1861 - 1879
12
Sarah C. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.12]
b. Apr 1862 d. 31 Dec 1929 [
=>
]
12
James N. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.13]
b. 1865 d. 5 Jul 1934 [
=>
]
12
Harriet Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.14]
b. 1867 d. Between 1881 - 1961
12
Andrew Jackson Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.15]
b. 06 Nov 1868 d. 24 Jun 1941 [
=>
]
12
Louisa Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.16]
b. 1871 d. Bet. 1871 - 1964
12
Susan Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.17]
b. 1873 d. Between 1873 - 1966
12
C. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.18]
b. 1877 d. Between 1877 - 1878
12
Marcus Sylvester Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.19]
b. 8 May 1877 d. 12 Apr 1965 [
=>
]
12
Elijah W. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.2.20]
b. Jul 1879 d. Between 1896 - 1969 [
=>
]
11
_____ Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.3]
b. 1824
11
_____ Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.4]
b. 1824 d. Bet. 1824 - 1918
11
_____ Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.5]
b. 1824
11
Martin Nathaniel Clabaugh, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6]
b. 1827 d. Nov 1898
Margaret Ogle
b. 1827 d. 29 Mar 1897
12
Isaac Taylor Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.1]
b. 19 Aug 1848 d. 29 Jan 1919 [
=>
]
12
Marriah Clabo
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.2]
b. 1850 d. 20 Mar 1887 [
=>
]
12
_____ Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.3]
b. 1853 d. Bet. 1853 - 1947
12
Susannah Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.4]
b. 1855 d. 1885 [
=>
]
12
James Newton Clabo
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.5]
b. 01 Aug 1857 d. 23 Dec 1941 [
=>
]
12
Martin Nathaniel Clabaugh, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.6]
b. 06 Aug 1859 d. 22 Dec 1927 [
=>
]
12
Margaret Clabo
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.7]
b. 1862 d. 1898 [
=>
]
12
William Sherman Clabo
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.6.8]
b. 05 Sep 1865 d. 24 May 1952 [
=>
]
11
Eliza Margaret Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7]
b. 22 Aug 1829 d. 16 Mar 1911
John Ogle
b. 18 Feb 1826 d. 20 Mar 1865
12
William M. Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.1]
b. 25 Aug 1851 d. 30 Jun 1913 [
=>
]
12
Madison Cates Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.2]
b. 6 Aug 1853 d. 4 Feb 1919 [
=>
]
12
_____ Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.3]
b. 1855 d. Abt 1855
12
Martha Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.4]
b. 1857 d. Bet. 1858 - 1951
12
John Ogle, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.5]
b. 1860 d. Bet. 1860 - 1949
12
_____ Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.6]
b. 1861 d. Bet. 1862 - 1955
12
Nancy Elizabeth Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.7.7]
b. 5 Jan 1863 d. Bet. 1877 - 1957
+
_____ Mize
b. Bet. 1812 - 1832 d. Bet. 1846 - 1918
11
Nancy Jane Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8]
b. 25 Nov 1830 d. 31 Dec 1912
Corporal James Johnathan Roberts
b. 30 Jun 1826 d. 22 Jun 1908
12
George Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.1]
b. 1849 d. Between 1849 and 1938
12
Margaret Elizabeth "Eliza" Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.2]
b. 17 Dec 1851 d. 19 Nov 1926 [
=>
]
12
Daniel Boone Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.3]
b. 08 Feb 1852 d. 18 Mar 1917 [
=>
]
12
William Elijah Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.4]
b. 20 Jan 1855 d. Between 1882 - 1947 [
=>
]
12
Samuel Joshua Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.5]
b. 24 Jun 1855 d. 27 Dec 1938 [
=>
]
12
Lavina Catherine Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.6]
b. 13 Nov 1861 d. 11 Sep 1930 [
=>
]
12
Sarah Ann Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.7]
b. 1863 d. 1886 [
=>
]
12
_____ Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.8]
b. 1866
12
Rebecca Frances Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.9]
b. 01 Oct 1867 d. 20 Jun 1937 [
=>
]
12
Jr. James Johnathan Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.10]
b. 20 Feb 1870 d. 24 Nov 1957 [
=>
]
12
Annie Elizabeth Roberts
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.8.11]
b. 19 Jan 1873 d. 22 Jan 1953 [
=>
]
11
Lavina Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9]
b. 08 Nov 1836 d. 06 Jan 1914
Robert Floyd, Sr.
b. 09 Oct 1831 d. 05 Apr 1912
12
Frances Floyd
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.1]
b. Between 1853 and 1879 d. Between 1858 and 1962
12
Richard N. Floyd
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.2]
b. Between 1854 and 1880 d. Between 1859 and 1959
12
Martha Floyd
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.3]
b. Between 1855 and 1881 d. Between 1858 and 1962
12
Robert Floyd, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.4]
b. Between 1856 and 1882 d. Between 1859 and 1959
12
Caldonia Floyd
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.5]
b. Between 1858 and 1884 d. Between 1858 and 1962
12
Elizabeth Floyd
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.9.6]
b. Bet. 1857 - 1883 d. Bet. 1858 - 1962
11
Marion C. Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10]
b. 1838 d. Between 1870 and 1929
Anna Butler
b. 22 Jul 1824 d. Bet. 1853 - 1936
12
Jemima Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10.1]
b. 1857 d. Between 1858 and 1951
12
McAjah Rogers Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10.2]
b. 1861 d. Between 1862 and 1951
12
William McClellan Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10.3]
b. 1863 d. Between 1864 and 1953
12
Mary Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10.4]
b. 1865 d. Between 1866 and 1959
12
_____ Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10.5]
b. Abt. 1867 d. Bet. 1868 - 1961
12
Mitchell McCown Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.10.6]
b. 1869 d. Between 1870 and 1959
11
Jackson Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.2.11]
b. 1840 d. Between 1840 and 1930
10
Wyley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3]
b. 17 Feb 1798 d. 11 May 1859
Margaret Adair
b. 4 Dec 1802 d. 3 Jun 1886
11
Mary Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1]
b. 08 Jun 1825 d. 04 Nov 1897
Private James Alexander McFalls
b. 1823 d. 28 Oct 1864
12
Elizabeth McFalls
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.1]
b. 31 Mar 1847 d. 21 Dec 1929 [
=>
]
12
Margaret McFalls
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.2]
b. 1849 d. 1915 [
=>
]
12
Mary McFalls
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.3]
b. 27 Dec 1850 d. 10 Apr 1918 [
=>
]
12
Arthur McFalls
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.4]
b. 26 Dec 1852 d. 02 Aug 1914 [
=>
]
12
Wyley McFalls
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.5]
b. 27 Jan 1855 d. Between 1872 - 1945 [
=>
]
12
Malinda Elizabeth McFalls
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.6]
b. 18 May 1857 d. 1923 [
=>
]
12
Rebecca McFalls
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.7]
b. 26 Dec 1859 d. 09 Mar 1865
12
Marcus Arline McFalls
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.8]
b. 14 Apr 1862 d. 24 Apr 1928 [
=>
]
Frank Smith
b. Aft 1824
12
Cynthia Ann Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.9]
b. Aft 1862
12
Deanna Marie Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.10]
b. Aft 1863
12
Russell Franklin Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.11]
b. Aft 1864
12
James Smith
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.1.12]
b. Aft 1865
11
Nathaniel Louis Wilson King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2]
b. 1 Jul 1827 d. 1876
Eve Rosanna Maples
b. 23 Dec 1830 d. 23 Dec 1920
12
James William King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.1]
b. Nov 1849 d. Between 1850 and 1939
12
Margaret King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.2]
b. Abt 1852
12
William W. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.3]
b. Abt 1855
12
Elizabeth Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.4]
b. 15 Apr 1857 d. 14 Feb 1940 [
=>
]
12
Sarah M. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.2.5]
b. Abt 1859
11
Charles Wesley King, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3]
b. 12 Aug 1829 d. Between 1875 - 1921
Elizabeth Cotter
b. 1829 d. 1857
12
Hannah King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.1]
b. 1849 d. Between 26 Jun 1868 and 31 Dec 1943
12
Margaret King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.2]
b. 1851 d. Between 1865 and 1945
12
William King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.3]
b. 1852 d. Bet. 1853 - 1942
12
Nancy King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.4]
b. 1854 d. Between 1868 and 1948
12
Wyley Valentine King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.5]
b. 1856 d. Abt 1940 [
=>
]
Martha Ann Cleeton
b. 1838 d. Between 1876 and 1933
12
James S. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.6]
b. 1859 d. 1939
12
Mary King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.7]
b. 1861 d. Bet. 1881 - 1955
12
Charles Wesley King, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.8]
b. 1863 d. Between 1880 - 1953
12
Sarah E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.9]
b. 1865 d. Between 1882 and 1959
12
Armilda King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.10]
b. 1867 d. Between 1884 and 1961
12
John Thomas King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.11]
b. 1869 d. Between 1870 and 1959
12
Josephine King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.12]
b. 1871 d. Bet. 1885 - 1965
12
Warren King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.3.13]
b. 15 Apr 1874 d. 23 Apr 1929
11
John Nicton King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4]
b. May 1831 d. Between 01 Jan 1901 and 30 Jan 1925
Nancy Elizabeth Nations
b. Aug 1831 d. Between 01 Jan 1876 and 30 Jan 1929
12
Wyley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.1]
b. 1852 d. Between 1853 and 1942
12
Harvey King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.2]
b. 22 Jan 1853 d. 02 May 1920 [
=>
]
12
George Washington King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.3]
b. 1856 d. Between 1875 and 1946
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.4]
b. 1858 d. Bet. 1859 - 1900
12
Joel King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.5]
b. 3 Oct 1858 d. 7 Jul 1939 [
=>
]
12
Margaret Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.6]
b. 1861
12
William Valentine King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.7]
b. Feb 1863
12
Charles Wesley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.8]
b. 1867
12
Greenberry B. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.9]
b. Apr 1870 [
=>
]
12
Thomas Preston King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.10]
b. Jan 1872 [
=>
]
12
Lewis Calvin King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.4.11]
b. 1876
11
Nancy E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5]
b. 05 Jul 1833 d. 11 Jan 1892
George Easerly Houser
b. 1834 d. 10 May 1863
12
Lemuel Lewis Houser
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.1]
b. 21 Oct 1857 d. 03 Apr 1913
12
Reverand George Sylvestor Houser
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.2]
b. 08 Sep 1859 d. 14 Mar 1948 [
=>
]
12
Reverand James Wesley Houser
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.3]
b. 28 Jan 1862 d. 22 Mar 1943 [
=>
]
Greenwood B. Nations
b. Abt 1837 d. 21 May 1898
12
Charles William Nations
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.4]
b. 28 Jan 1868 d. 31 Jul 1951
12
Margaret Ann Nations
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.5]
b. 29 May 1870 d. 29 Jun 1941 [
=>
]
12
John Wiley Nations
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.5.6]
b. 13 Aug 1871 d. 03 Jul 1952
11
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.6]
b. 1 Jan 1835 d. 1 Jan 1835
11
Wiley Valentine King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.7]
b. 14 Feb 1838 d. 3 Dec 1862
Caroline B. Cotter
b. 1828 d. 19 May 1907
12
Martha Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.1]
b. 08 Nov 1860 d. Between 1860 and 1954
12
William Alexander King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.7.2]
b. 24 Mar 1862 d. Between 1863 and 1952
11
James Sylvester King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.8]
b. 14 Feb 1838 d. 29 Mar 1865
Louisa Marriah Cotter
b. 03 Mar 1831 d. Between 1863 and 1925
12
Margaret Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.1]
b. 23 Jul 1860
12
Nancy Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.8.2]
b. 03 Feb 1862
11
Mary Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9]
b. 12 Apr 1840 d. 10 Jul 1897
Daniel Wesley Stephen Reagan, Jr.
b. 11 Sep 1840 d. 21 Feb 1914
12
James Valentine Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.1]
b. 26 Apr 1860 d. 30 Oct 1927 [
=>
]
12
Charles Wesley Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.2]
b. 10 Feb 1866 d. 18 Jul 1955 [
=>
]
12
Daniel Kemuel Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.3]
b. 18 Oct 1868 d. 11 May 1935
12
William Wyley Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.4]
b. 28 Apr 1871 d. 27 Jun 1931
12
Lemuel Edward Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.5]
b. 08 Oct 1873 d. 01 Jul 1932 [
=>
]
12
George Sylvestor Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.6]
b. 24 Jul 1877 d. 12 Sep 1880
12
Mary Emmiline Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.7]
b. 08 Sep 1879 d. 29 Oct 1879
12
Marcus Leviticus Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.9.8]
b. 9 Mar 1883 d. Bet. 1916 - 1973
11
Sarah Malinda Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10]
b. 13 Apr 1842 d. 4 Jan 1914
William Calvin Hardin, Sr.
b. 1837 d. 1864
12
John Harvey Hardin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.1]
b. 14 Oct 1860 d. 06 May 1916 [
=>
]
12
William Calvin Hardin, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.2]
b. 16 Feb 1863 d. 30 Dec 1938
William Walker
b. 25 Oct 1842 d. 06 Nov 1918
12
John H. Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.3]
b. 1861
12
William C. Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.4]
b. 1863
12
Thomas Berton Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.5]
b. 28 Nov 1867 d. 09 Jun 1949
12
Wiley Valentine Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.6]
b. 17 Sep 1869 d. 29 Jun 1950
12
Margaret Malinda Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.7]
b. 03 Jan 1872 d. 11 Feb 1942
12
Eliza Elizabeth Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.8]
b. 10 Mar 1874 d. 24 Feb 1965
12
George Daniel Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.9]
b. 10 Apr 1877 d. 19 Mar 1941
12
Martha Jane Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.10.10]
b. 14 May 1881 d. 03 Mar 1952
11
Margaret Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11]
b. 18 Jul 1846 d. 15 Jan 1909
John N. Walker
b. 03 Mar 1841 d. 13 Apr 1921
12
Deacon Willliam Wiley Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.1]
b. Aft. 29 Mar 1866 d. 5 Feb 1925 [
=>
]
12
John Henry Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.2]
b. Aft 29 Mar 1866 d. 6 Dec 1942 [
=>
]
12
Martha Ann Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.3]
b. Aft 29 Mar 1866 d. 26 Jul 1951
12
Louisa Susan Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.4]
b. Aft. 29 Mar 1866 d. 13 Jul 1964
12
Hettie Rebecca Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.5]
b. Aft. 29 Mar 1866
12
James Thomas Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.6]
b. 22 Feb 1867 d. 21 Jun 1944 [
=>
]
12
Margaret Jane Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.7]
b. 29 Aug 1870 d. 20 Dec 1962
12
Mary Elizabeth Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.8]
b. 6 Feb 1875 d. 13 Jun 1945
12
Nancy Malinda Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.9]
b. 31 Jan 1880 d. 02 Jul 1931
12
Sarah Caroline Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.10]
b. 06 Feb 1886 d. 05 Feb 1966 [
=>
]
12
Hettie Rebecca Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.11]
b. 04 Jul 1889 d. 24 Dec 1947
12
Private Giles Daniel Walker
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.3.11.12]
b. 10 Oct 1891 d. 18 Apr 1971
10
William Riley King, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4]
b. 1803 d. 1881
Ellender Keller
b. 1808 d. Bet. 1881 - 1902
11
Lavina Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1]
b. 22 Apr 1825 d. 22 Feb 1915
Henry Franklin
b. 23 Aug 1820 d. 31 Jan 1907
12
Hiram Hodsden Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.1]
b. 06 Jan 1846 d. 16 Aug 1920 [
=>
]
12
Lucinda Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.2]
b. 1848 d. 19 Jun 1907 [
=>
]
12
Elizabeth Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.3]
b. 1850
12
William Runnels Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.4]
b. 14 May 1851 d. 24 May 1947 [
=>
]
12
Henry Jackson Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.5]
b. 26 Dec 1852 d. 25 Nov 1938 [
=>
]
12
Sarah Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.6]
b. 1855
12
Lavina Ann Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.7]
b. 18 Nov 1856 d. 14 Jan 1908 [
=>
]
12
John R. Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.8]
b. 18 Nov 1856 d. Between 1899 - 1948 [
=>
]
12
Reverand Nathaniel W. Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.9]
b. 12 Apr 1858 d. 07 Jun 1943 [
=>
]
12
Margaret Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.10]
b. 1859
12
Isaac Taylor Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.11]
b. 28 Sep 1861 d. 30 Aug 1913 [
=>
]
12
Mary Jane Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.12]
b. 1865
12
Sophia J. Franklin
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.1.13]
b. Jul 1867 d. Aft 1902 [
=>
]
11
Lucinda Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2]
b. 5 Jan 1826 d. 24 May 1904
William D. Maples
b. 1827 d. 3 Feb 1898
12
Ellender Nellie Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.1]
b. 14 Sep 1846 d. 26 Nov 1924 [
=>
]
12
Abijah Bige Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.2]
b. May 1847 d. Aft 1900 [
=>
]
12
Elijah Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.3]
b. Abt 1848 d. Between 1849 and 1938
12
Sarah E. Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.4]
b. 1849 d. Bef 1864
12
Lavina Ann Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.5]
b. 03 Nov 1851 d. 19 Nov 1922 [
=>
]
12
David Crockett Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.6]
b. 7 Apr 1857 d. 3 Jun 1877
12
Eva Roseann Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.7]
b. 1859 d. Bet. 1893 - 1899 [
=>
]
12
Lucinda Catherine Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.8]
b. 1862 d. 1940 [
=>
]
12
Nancy Ezalee Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.9]
b. 24 Mar 1868 d. 6 Oct 1923 [
=>
]
12
Rev. Lewis Howard Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.2.10]
b. 05 Apr 1869 d. 03 Aug 1945 [
=>
]
11
William Riley King, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3]
b. Jul 1828 d. Bet. 1901 - 1931
Matilda Ogle
b. May 1829 d. 10 Sep 1891
12
Sarah Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.1]
b. 1847 d. 1871 [
=>
]
12
Nancy Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.2]
b. 1849 d. 1940 [
=>
]
12
Isaac King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.3]
b. Feb 1851 d. Bet. 1893 - 1942 [
=>
]
12
Susan A. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.4]
b. 10 Feb 1852 d. 22 May 1922 [
=>
]
12
Mary Malinda King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.5]
b. 14 Mar 1852 d. 30 Jan 1933 [
=>
]
12
William Riley King, III
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.6]
b. 23 Feb 1854 d. 22 Jun 1939 [
=>
]
12
Nathaniel Wyley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.7]
b. 1857 d. Bet. 1891 - 1947 [
=>
]
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.8]
b. 1859
12
Lucinda King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.9]
b. 22 May 1861 d. 26 Sep 1934 [
=>
]
12
Matilda King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.10]
b. 1863 d. 1891 [
=>
]
12
Samuel King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.3.11]
b. Jun 1867 d. 1932 [
=>
]
11
Nathaniel Wiley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4]
b. 28 May 1830 d. 5 Mar 1921
Alpha Ogle
b. 1832 d. Mar 1860
12
Mary Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.1]
b. 22 Jul 1849 d. 25 Jan 1926 [
=>
]
12
William Riley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.2]
b. 14 Oct 1850 d. 15 Feb 1940 [
=>
]
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.3]
b. Abt 1853 d. Abt 1853
12
Nathaniel W. Y. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.4]
b. 7 Feb 1855 d. 24 Aug 1936 [
=>
]
12
Henry Russell King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.5]
b. Oct 1857 d. Bet. 1899 - 1948 [
=>
]
12
Alpha King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.6]
b. Abt Mar 1860 d. 15 Jan 1927 [
=>
]
Barbara Henry
b. 21 Mar 1840 d. 02 Feb 1911
12
Alfred King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.7]
b. 1862 d. Between 1901 and 1952
12
John J. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.8]
b. 1864 d. Between 1865 and 1954
12
Allen King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.9]
b. Jun 1866 d. 19 Sep 1941 [
=>
]
12
David D. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.10]
b. 22 Mar 1867 d. 11 Mar 1950 [
=>
]
12
Hugh L. B. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.11]
b. 1869 d. Between 1870 and 1959
12
Joel Brooks King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.12]
b. 25 Jan 1871 d. 1 May 1928 [
=>
]
12
Reverand James Elder Jim King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.13]
b. 18 Jan 1873 d. 21 Dec 1943 [
=>
]
12
Lania Ellen King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.14]
b. Apr 1875 d. Between 1919 - 1970 [
=>
]
12
Lewis Nicanor King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.15]
b. 18 Sep 1877 d. 30 Apr 1951 [
=>
]
12
Sarah E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.4.4.16]
b. 1879 d. Between 1879 and 1973
10
George Washington King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5]
b. 10 Apr 1806 d. 19 Dec 1857
Anna Pendgrass
b. Abt 1836
11
Nancy Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.1]
b. 6 Dec 1826 d. Bet. 1848 - 1937
+
Thomas Baker
b. Bet. 1820 - 1834 d. Aft. 1860
11
Elizabeth Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.2]
b. 22 Nov 1828 d. Aft 1842
+
Wright Riden
b. Aft 1826 d. Aft 1842
11
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.3]
b. Bet. 1824 - 1850 d. Bet. 1829 - 1933
11
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.4]
b. Bet. 1826 - 1855 d. Bet. 1831 - 1937
Rebecca Slaughter
b. 19 Mar 1806 d. 15 Apr 1882
11
Corporal William Henry King, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5]
b. 18 Jan 1832 d. 8 Oct 1912
Caroline Satilla Simpson
12
Forrest Grady King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.1]
12
Birdie Mae King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.2]
12
John Madison King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.3]
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.4]
12
Corine Trammel King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.5]
12
Carolyn Satilla King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.6]
12
William Henry King, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.7]
12
Pauline King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.8]
12
Annie Arazona King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.9]
12
Arthur Lee King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.10]
12
Warren Chester King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.11]
Martha Jane Headrick
b. 13 Sep 1832 d. 10 Jun 1935
12
Elizabeth Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.12]
b. 03 Dec 1851 d. 29 Aug 1905 [
=>
]
12
M. S. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.13]
b. Aft 1851 d. Yes, date unknown
12
James Thomas King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.14]
b. 12 Jun 1852 d. 22 Jul 1930 [
=>
]
12
Rebecca Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.15]
b. 01 Mar 1855 d. 21 Feb 1946 [
=>
]
12
George Washington King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.16]
b. 03 Feb 1857 d. 18 Mar 1918 [
=>
]
12
Mary Minerva King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.17]
b. 11 Jan 1859 d. 20 Apr 1954 [
=>
]
12
Martha Louisa King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.18]
b. 03 Jan 1861 d. 29 Jun 1955 [
=>
]
12
Nancy Caroline King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.19]
b. 25 Apr 1866 d. 13 Aug 1890 [
=>
]
12
Daniel Jackson King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.20]
b. 26 Dec 1867 d. 29 Jan 1939 [
=>
]
12
Sarah Ellen King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.21]
b. 07 Nov 1869 d. 15 Jul 1963 [
=>
]
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.22]
b. Abt 1871
12
John Wiley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.23]
b. 1 Feb 1873 d. 2 Jul 1941 [
=>
]
12
Hettie Texas King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.24]
b. 10 Jul 1875 d. 13 Dec 1956 [
=>
]
12
Hulda Ida King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.5.25]
b. 31 Jul 1878 d. 16 Apr 1963 [
=>
]
11
Sarah Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.6]
b. 22 Nov 1833 d. Bet. 1847 - 1937
+
_____ Rider
b. Aft 1830
11
Nathaniel Jackson King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.7]
b. 10 Dec 1835 d. 14 Dec 1850
11
George Alexander King, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.8]
b. 25 Dec 1837 d. 02 Nov 1893
Nancy Jane Caylor
b. 06 Feb 1841 d. 02 Jan 1929
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.8.1]
b. 1861 d. 1861
12
Annie R. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.8.2]
b. 1863
12
Martha J. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.8.3]
b. 1865
12
George Alexander King, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.8.4]
b. 1868
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.8.5]
b. 1870 d. 1870
12
Mary A. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.8.6]
b. 1872
11
Malvina Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.9]
b. 5 Jan 1841 d. Bet. 1854 - 1861
+
John Cotter
b. Aft 1839
11
John Wiley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10]
b. 08 Mar 1843 d. 29 May 1910
Elmina Cooper
b. 1845 d. Aft 1877
12
Wiley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10.1]
b. 1867
12
Dixie King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10.2]
b. 1868
12
Edgar Bruce King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10.3]
b. 1869
12
James Walton King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10.4]
b. 1870
12
Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10.5]
b. 1871
12
Callie King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10.6]
b. 1873
12
William Booth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10.7]
b. 1875
12
Benjamin King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10.8]
b. 1877
+
Frances Davis
b. 1845 d. Aft 1866
Mary Ann Gadberry
b. Bet. 1842 - 1860 d. Aft 1873
12
Joseph Wiley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.10.9]
b. 1873 d. 1925 [
=>
]
11
Abraham Bennett King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11]
b. 21 Apr 1845 d. 13 Feb 1917
Sarah Malinda Davis
b. 23 Jan 1847 d. 16 Oct 1908
12
John Wiley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.1]
b. 1869
12
Ellen Rebecca King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.2]
b. Aft 1868
12
Carrie Belle King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.3]
b. Aft 1868
12
Louis Francis King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.4]
b. Aft 1868 d. Aft 1898
12
James Elbert King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.5]
b. Aft 1868
12
Harvey Madison King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.6]
b. Aft 1868
12
George H. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.7]
b. Abt 1870 d. Aft 1872
12
Edgar King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.8]
b. 1871
12
Malinda Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.9]
b. 1873
12
Sara Caldonia King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.10]
b. 1875
12
William Henry King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.11]
b. 1877
12
Abraham Benjamin King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.11.12]
b. 1879
11
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.12]
b. Bet. 1824 - 1850 d. Bet. 1829 - 1933
11
James Thomas King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13]
b. 17 Aug 1851 d. 24 Nov 1934
Mary Catherine Walker
b. 30 Jan 1856 d. 04 Jun 1930
12
George Wiley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.1]
b. 27 Jun 1873 d. 08 Dec 1956 [
=>
]
12
Joseph Robert King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.2]
b. 21 Dec 1875 d. 1970 [
=>
]
12
Sarah Rebecca King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.3]
b. 02 Nov 1877 d. 26 Jun 1936 [
=>
]
12
Susan Catherine King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.4]
b. 05 Dec 1880 d. 17 May 1960 [
=>
]
12
Nancy Malinda King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.5]
b. 28 Jul 1883 d. 26 Jul 1936
12
Mary Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.6]
b. 27 Mar 1886 d. 11 Apr 1959 [
=>
]
12
Myrtle Harrison King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.7]
b. 03 Mar 1889 d. 24 Aug 1936 [
=>
]
12
Martha Alice King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.8]
b. 28 Nov 1891 d. 06 Oct 1954
12
Anna Benson King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.9]
b. 23 Feb 1893 d. 28 Oct 1961
12
Lena Emaline King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.10]
b. 2 Dec 1898
12
Rose Ellen King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.13.11]
b. 26 Jul 1904 d. 06 Jun 1964
11
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.5.14]
b. Bet. 1826 - 1855 d. Bet. 1831 - 1937
10
Nancy Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6]
b. 1807 d. 27 Nov 1877
John Brickey
b. 1805 d. 5 Feb 1873
11
Elizabeth Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1]
b. 16 Nov 1832 d. 08 Jun 1891
George Thomas Caylor, Sr.
b. 28 Oct 1834 d. 25 Feb 1899
12
William R. Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.1]
b. 07 Feb 1865 d. 28 Dec 1945 [
=>
]
12
Susan C. Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.2]
b. 18 Feb 1867 d. 22 Jul 1898 [
=>
]
12
James H. Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.3]
b. 02 Dec 1868
12
Nancy Jane Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.4]
b. 14 Jan 1870
12
Daniel Jackson Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.5]
b. 21 May 1872 d. 05 Jun 1950 [
=>
]
12
George Thomas Caylor, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.1.6]
b. 20 May 1876 d. 12 Mar 1971 [
=>
]
11
Eleanor Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.2]
b. 27 Dec 1833 d. 08 Jul 1917
+
Daniel Caylor
b. 22 Jul 1835 d. 15 Nov 1924
11
William Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3]
b. 05 Oct 1835 d. 07 Apr 1916
Susannah Caylor
b. 05 Sep 1839 d. 02 Feb 1927
12
John Houston Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.1]
b. 26 Jan 1861 d. 1919 [
=>
]
12
Francis Marion Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.2]
b. 26 Jan 1861 d. 31 Jan 1884
12
George Washington Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.3]
b. 24 Mar 1868 d. 31 Mar 1919 [
=>
]
12
Martha Susan Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.4]
b. 17 Jan 1870 d. 30 Jul 1916 [
=>
]
12
William Peter Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.5]
b. 11 May 1871 d. 13 Jul 1894
12
Wiley Jackson Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.6]
b. 11 Nov 1874 d. 13 Apr 1900
12
Anna Mariam Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.7]
b. 26 Jun 1877 d. 23 Jan 1878
12
Nancy Margaret Jane Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.8]
b. 17 Jan 1879
12
Mary Elizabeth Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.9]
b. 16 Oct 1881
12
Sarah Eleanor Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.3.10]
b. 24 May 1885 d. 22 Feb 1948
11
Martha Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4]
b. 25 Mar 1838 d. 12 Oct 1887
Lazarus Oliver
b. 1827 d. 1902
12
Martha Jane Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.1]
b. Abt 1878
12
John B. Oliver
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.4.2]
b. 09 May 1880 d. 29 Aug 1924 [
=>
]
11
Mary Jane Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5]
b. 05 May 1840 d. 24 Jul 1921
Benjamin Franklin Abbott
b. 07 Jul 1833 d. Aft 1883
12
George Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.1]
b. Aft 1861
12
Nathaniel Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.2]
b. 27 Jun 1862
12
Annis Rebecca Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.3]
b. 04 Dec 1868
12
Martha Angeline Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.4]
b. Abt 1870
12
Nancy Elizabeth Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.5]
b. Abt 1872
12
John Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.6]
b. Abt 1874
12
Alice Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.7]
b. Abt 1876
12
Hettie Cordelia Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.8]
b. Abt 1878
12
Noah Jackson Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.9]
b. 15 Dec 1879
12
William Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.10]
b. 26 Aug 1880 d. Oct 1963
12
Charles Abbott
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.5.11]
b. Abt 1883
11
Peter Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.6]
b. 1842 d. 1864
11
John Brewer Jackson Brickey, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7]
b. 1845 d. 1916
Martha Caylor
b. 1851 d. 1890
12
Nancy Texanna Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.1]
b. 1869
12
William Alexander Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.2]
b. 18 Feb 1870 d. 25 Oct 1949
12
Annie Eleanor Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.3]
b. 1872
12
George Washington Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.4]
b. 1875
12
John Brewer Jackson Brickey, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.5]
b. 1877
12
Daniel Lafayette Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.6]
b. 1879
12
Martha Lucinda Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.7]
b. Abt 1881
12
Jessie Peter Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.8]
b. Abt 1883
12
Jarrett Marion Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.9]
b. Abt 1885
12
Mary Elizabeth Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.10]
b. 21 Apr 1889 [
=>
]
Laura Emaline Devine Kitts
b. 1859
12
Audrey Susan Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.11]
b. Aft 1873
12
Lilland M. L. Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.12]
b. Aft 1873
12
Leonard H. Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.7.13]
b. Aft 1873
11
George Washington Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.8]
b. 1847 d. 12 Dec 1875
11
Jesse D. Wiley Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.9]
b. 1850 d. 1875
Malvina Wear
b. 08 Apr 1851 d. 25 Mar 1925
12
Nancy Ann Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.9.1]
b. Aft 1869
12
Sarah Jane Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.9.2]
b. 19 May 1870 d. 17 Nov 1907 [
=>
]
12
Nancy Adeline Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.9.3]
b. 24 Dec 1871 d. 12 Dec 1941 [
=>
]
11
Nancy Leannah Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10]
b. 10 Jun 1853 d. 05 Aug 1917
Daniel Caylor
b. 24 Mar 1851 d. 09 Apr 1924
12
George W. Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.1]
b. 06 Jun 1872 d. 27 Oct 1898
12
Lydia Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.2]
b. 12 Jun 1874 d. 12 Jun 1929
12
Andrew Jackson Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.3]
b. 12 Dec 1876 d. 07 Jun 1950
12
Eli Alexander Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.4]
b. 30 Oct 1878 d. 22 May 1922 [
=>
]
12
Sarah Alice Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.5]
b. 28 Apr 1881 d. 08 May 1964 [
=>
]
12
William Peter Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.6]
b. 19 Aug 1883 d. 13 Dec 1949 [
=>
]
12
Susan Jane Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.7]
b. 09 Mar 1886 d. 10 Dec 1912
12
James W. Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.8]
b. 17 Jan 1890
12
John M. Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.9]
b. 29 Aug 1892
12
Martha Ellen Caylor
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.10.10]
b. 2 Nov 1895
11
Sarah Melvina Brickey
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.6.11]
b. 1855 d. Between 24 Jul 1871 and 1940
+
James Robert Rosson
b. Aft 1853 d. Aft 24 Jul 1871
10
Nathaniel M. King, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7]
b. 1808 d. Bet. 1857 - 1899
Sarah Ogle
b. 1817 d. 1880
11
Susanna King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1]
b. 15 Mar 1834 d. 12 Feb 1908
Ira Whaley
b. Apr 1831 d. 1908
12
Martha Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.1]
b. 25 Sep 1843 d. 27 Dec 1912 [
=>
]
12
Sarah Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.2]
b. Aft 1843
12
_____ Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.3]
b. Aft 1843
12
Pleasant W. Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.4]
b. 1854
12
_____ Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.5]
b. 1856
12
George Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.6]
b. 1858
12
Margaret Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.7]
b. 1860
12
_____ Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.8]
b. 1862
12
Nancy E. Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.9]
b. 1864
12
Isaac Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.10]
b. 1866
12
_____ Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.11]
b. Abt 1868
12
William Bradford Whaley
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.1.12]
b. 1872
11
Margaret King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2]
b. 1836 d. Between 1880 - 1930
Pleasant Proffitt
b. 1826 d. 1891
12
John Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.1]
b. 1852
12
John Jackson Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.2]
b. Feb 1854 d. Between 1875 and 1944 [
=>
]
12
David L. Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.3]
b. 1855 d. 07 Jan 1928
12
William H. Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.4]
b. Abt 1857
12
_____ Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.5]
b. Abt 1858
12
_____ Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.6]
b. Abt 1860
12
William N. Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.7]
b. 24 Dec 1862 d. 1939
12
Isaac Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.8]
b. 29 Aug 1865 d. 22 Dec 1935
12
Martha Jane Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.9]
b. 15 Jan 1867
12
Mary Ellen Proffitt
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.2.10]
b. 15 Apr 1870
+
Dr. Dave Waters
b. Between 1834 - 1837
11
Nancy Adeline King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3]
b. 1838 d. 10 Feb 1892
Sargent James Madison Maples
b. 24 Mar 1837 d. 31 Oct 1916
12
George P. Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.1]
b. 02 Nov 1858 d. 23 Mar 1930 [
=>
]
12
Nathaniel Redmond Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.2]
b. 01 May 1860 d. Between 1898 and 1951 [
=>
]
12
James Abijah Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.3]
b. 14 Jan 1863 d. 23 Jan 1925 [
=>
]
12
Isaac R. Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.4]
b. 01 May 1866 d. 01 Dec 1935 [
=>
]
12
David Crockett Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.5]
b. 1868 d. Bet. 1883 - 1958
12
Mary Roseann Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.6]
b. 1870 d. Bet. 1885 - 1964
12
Lucy E. Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.7]
b. 1872 d. Between 1873 and 1966
12
Isey Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.8]
b. 1875 d. 1875
12
William Thomas Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.9]
b. 12 Oct 1877 d. 22 Nov 1938 [
=>
]
12
John Mitchell Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.10]
b. 14 Jun 1879 d. 5 Jul 1947
12
Martha Ann Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.11]
b. 28 May 1881 d. Between 1895 and 1975
12
James Lawson Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.12]
b. 13 Feb 1883 d. 12 May 1935 [
=>
]
12
Mitchell Redman Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.13]
b. May 1886 d. Between 1906 and 1977
12
Maranda L. Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.14]
b. Jun 1889 d. Between 1890 and 1983
12
Nancy M. Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.15]
b. Jun 1889 d. Bet. 1890 - 1983
12
William Houk Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.16]
b. Jun 1891 d. Between 1892 and 1981
12
Sarah Narcissa Maples
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.3.17]
b. Jun 1891 d. 5 May 1986 [
=>
]
11
Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4]
b. 1840 d. 02 Oct 1864
Jackson C. Stinnett
b. 24 Feb 1838 d. 1912
12
Margaret Stinnett
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.1]
b. 1861
12
Lucinda Stinnett
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.2]
b. 1863
12
Sarah Stinnett
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.3]
b. Abt 1864
12
_____ Stinnett
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.4.4]
b. Abt 1865
11
Diana King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5]
b. Apr 1842 d. 14 Jul 1906
+
Sanders Williams
b. 1840 d. BET. 21 Sep 1863 - 23 Mar 1866
Joel S. Ogle
b. 1 Sep 1845 d. 7 Mar 1907
12
Sarah M. Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.1]
b. 1867 d. 07 Oct 1892 [
=>
]
12
Levi Hamilton Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.2]
b. Apr 1869 d. 10 Aug 1923 [
=>
]
12
Lawson Nathaniel Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.3]
b. 9 Aug 1872 d. 14 Mar 1952 [
=>
]
12
Rebecca J. Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.4]
b. 1875 d. 1951 [
=>
]
12
_____ Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.5]
b. Abt 1878
12
Nancy F. Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.6]
b. Jun 1882 d. Between 1883 and 1976
12
Martha Arlena Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.7]
b. Mar 1884 d. 29 May 1943 [
=>
]
12
Ida A. Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.8]
b. Mar 1886 d. Between 1887 and 1980
12
Minnie L. Ogle
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.5.9]
b. Oct 1888 d. Between 1889 and 1982
11
Isaac King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6]
b. 25 May 1844 d. 02 Jan 1897
Mary Ann Reagan
b. 22 Mar 1845 d. 6 Aug 1913
12
William Harrison King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.1]
b. 1866
12
Daniel Wesley King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.2]
b. 18 Aug 1868 d. 14 Sep 1926 [
=>
]
12
Sarah Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.3]
b. 24 Aug 1870 d. 21 Oct 1958
12
John Walker King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.4]
b. 16 Jan 1873 d. 07 Jul 1888
12
Charles Henry King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.5]
b. 12 Mar 1875 d. 22 Jul 1951
12
Mary Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.6.6]
b. 23 May 1877 d. Jul 1953
11
William Ford King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7]
b. 18 Nov 1846 d. 06 Nov 1938
Martha Ownby
b. 22 Feb 1852 d. 2 Feb 1932
12
Sarah Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.1]
b. 17 Nov 1868 d. 05 Sep 1904 [
=>
]
12
Lewis M. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.2]
b. 16 Apr 1871 d. 05 Jan 1954 [
=>
]
12
Sophia Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.3]
b. 10 Jun 1874 d. 09 Feb 1925 [
=>
]
12
Mary Rosetta King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.4]
b. Aug 1876 d. Yes, date unknown [
=>
]
12
Isaac N. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.5]
b. Nov 1878 d. Yes, date unknown
12
William Richard King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.6]
b. Apr 1882 d. Yes, date unknown
12
John Loy King, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.7]
b. 25 Apr 1885 d. 30 Dec 1967 [
=>
]
12
Martha Cordie King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.8]
b. 20 Nov 1887 d. 08 Feb 1970 [
=>
]
12
James Harrison King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.9]
b. 03 May 1890 d. 21 Sep 1960 [
=>
]
12
Samuel W. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.7.10]
b. Feb 1893 d. Yes, date unknown
11
Nathaniel M. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8]
b. 15 Mar 1848 d. 8 Feb 1935
Louisa Eliz Newman
b. 1840 d. 1886
12
Ellen Martha King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.1]
b. 1873 d. Between 1887 and 1967
12
John E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.2]
b. 1875 d. Between 1876 and 1965
12
James E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.3]
b. 1877 d. Between 1894 and 1967
12
Eliza Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.4]
b. 01 Apr 1879 d. 06 Jan 1969 [
=>
]
Ellen Newman
b. May 1865 d. 06 Dec 1922
12
Martha E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.5]
b. Nov 1888 d. Between 1889 and 1982
12
William Harrison King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.6]
b. 3 Jul 1890 d. 14 Apr 1983
12
Jude William Harrision King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.7]
b. 03 Jul 1890 d. 14 Apr 1983 [
=>
]
12
Nathaniel Earnest King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.8]
b. Jan 1892 d. Bet. 1892 -1982
12
Charles King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.9]
b. Nov 1895 d. Between 1896 and 1985
12
Isaac Garfield King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.10]
b. 3 Jan 1898 d. 14 Jun 1978
12
Beatrice King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.8.11]
b. 1901 d. Bet. 1921 - 1988
11
Sarah King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.9]
b. 25 Apr 1850 d. 03 Jul 1924
Samuel Hamner Newman
b. 04 Jan 1846 d. 02 Jan 1928
12
W. Pinkney Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.9.1]
b. 1872 d. Between 1890 and 1962
12
John Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.9.2]
b. 29 Jun 1875 d. 16 May 1946 [
=>
]
12
Martha Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.9.3]
b. 1879 d. Between 1893 - 1976
12
William Giles Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.9.4]
b. 1882 d. Aft 1903 [
=>
]
12
Samuel Wesley Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.9.5]
b. 1886
12
James N. Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.9.6]
b. 1889
11
Mary Ann King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.10]
b. 1852 d. 4 Dec 1925
Stuart Newman
b. 1852 d. Bet. 1921 - 1941
12
William R. Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.10.1]
b. 1871
12
Sarah J. Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.10.2]
b. 1873
12
Laura Jane Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.10.3]
b. Jun 1873 [
=>
]
12
_____ Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.10.4]
b. Abt 1875
12
_____ Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.10.5]
b. Abt 1877
12
_____ Newman
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.10.6]
b. Abt 1879
11
Phebia E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.11]
b. 1854 d. Between 1881 and 1948
William Brownlow Reagan
b. 18 Oct 1850 d. 20 Jul 1879
12
Sarah Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.11.1]
b. 1875 d. Between 1876 and 1969
12
Bruce Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.11.2]
b. 1876 d. 02 May 1938 [
=>
]
12
Mary M. Reagan
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.11.3]
b. 1877 d. Bet. 1905 - 1971 [
=>
]
11
Pleasant King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.12]
b. Mar 1856 d. Bet. 1914 - 1946
Deborah Malinda Dodgen
b. 1865 d. Bet. 1890 - 1895
12
Samuel A. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.12.1]
b. Mar 1881
12
Sarah Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.12.2]
b. Jan 1883 d. 21 Apr 1952
12
Mary Alice King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.12.3]
b. 5 Jul 1884 d. 28 May 1941
12
Armintha King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.12.4]
b. 10 Dec 1886 d. Oct 1970
12
Lillie D. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.12.5]
b. Nov 1889
Ruthie Callie Morgan
b. Aug 1875
12
Margaret King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.12.6]
b. May 1897
12
Martha E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.12.7]
b. Apr 1899
12
William M. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.7.12.8]
b. 15 Oct 1903 d. 21 Dec 1977 [
=>
]
+
Matilda _____
b. Bet. 1852 - 1872 d. Bet. 1873 - 1956
10
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.8]
b. 1810 d. Bet. 1810 - 1904
10
Elizabeth Catherine King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9]
b. 1812 d. 25 Oct 1863
Jacob Wesley Slaughter
b. 17 Apr 1803 d. Dec 1885
11
Nathaniel Mateson Eddington Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1]
b. 02 Aug 1830 d. 26 Jun 1908
Amanda Wiggins
b. Abt 1830 d. 18 Apr 1919
12
Maggie Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.1]
b. 18 Nov 1869
12
Lillie Ann Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.2]
b. 23 Dec 1872 d. Bef 1900
12
Robert Bruce Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.3]
b. 30 Mar 1875
12
Arabella Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.4]
b. 07 Oct 1877
12
Jacob Eddington Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.1.5]
b. 01 May 1882
11
George Lafayette Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2]
b. Oct 1832 d. Feb 1902
Martha Chambers
b. 1836 d. Aft 1900
12
James Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.1]
b. Aft 1858
12
Frank Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.2]
b. Aft 1859
12
Dewitt Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.3]
b. Aft 1860
12
Hazeltine Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.4]
b. Aft 1861
12
Mateson Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.5]
b. Aft 1862
12
Andrew Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.6]
b. Aft 1863
12
Alice Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.7]
b. Aft 1864
12
Elizabeth Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.8]
b. Aft 1865
12
Josephine Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.9]
b. Aft 1866
12
George Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.10]
b. Aft 1867
12
Pearl Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.2.11]
b. Aft 1868
11
Sarah Elizabeth Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3]
b. 22 Oct 1834 d. Feb 1902
George William Snyder
b. 28 Jun 1832 d. 19 May 1862
12
Sameul Snyder
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3.1]
12
Jacob Snyder
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3.2]
12
George William Snyder, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3.3]
12
Josephine Snyder
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3.4]
12
George Lafayette Snyder
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3.5]
12
Mary Snyder
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3.6]
12
James Snyder
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.3.7]
+
William Davis
b. Aft 1832
11
Nancy Catherine Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4]
b. 1837 d. 1915
Isaac T. Rose
b. 1833 d. Aft 1880
12
Sydney B. Rose
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.1]
b. Abt 1862
12
William A. Rose
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.2]
b. Abt 1864
12
Mary E. Rose
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.3]
b. Abt 1866
12
Albert J. Rose
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.4]
b. Abt 1868
12
Sarah L. Rose
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.5]
b. Abt 1870
12
Martha J. Rose
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.6]
b. Abt 1872
12
Wilburn M. Rose
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.7]
b. Abt 1873
12
James Rose
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.4.8]
b. Abt 1875
11
Isaac Jackson Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5]
b. 10 Nov 1840 d. 10 Nov 1912
Laura Sherrill
b. 1844
12
William Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.1]
b. Aft 1858
12
Charles Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.2]
b. Aft 1859
12
Carrie Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.3]
b. Aft 1860
12
Georgia Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.4]
b. Aft 1861
12
Elizabeth Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.5]
b. Aft 1862
12
Samuel Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.6]
b. Aft 1863
12
Jackson Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.7]
b. Aft 1864
12
Coleman Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.8]
b. Aft 1865
12
Winnie Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.9]
b. Aft 1866
12
Fannie Slaughter
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.9.5.10]
b. Aft 1867
10
ANDREW JACKSON KING, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10]
b. 1818 d. 15 Mar 1891
Lucinda Cynthia Rainwater
b. 1823 d. Bet. 1883 - 1899
11
Nancy Adeline King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1]
b. Dec 1839 d. 1900
James R. Clabough
b. 1822 d. 1900
12
_____ Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.1]
b. 1861 d. Bet. 1861 - 1879
12
Sarah C. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.2]
b. Apr 1862 d. 31 Dec 1929 [
=>
]
12
James N. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.3]
b. 1865 d. 5 Jul 1934 [
=>
]
12
Harriet Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.4]
b. 1867 d. Between 1881 - 1961
12
Andrew Jackson Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.5]
b. 06 Nov 1868 d. 24 Jun 1941 [
=>
]
12
Louisa Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.6]
b. 1871 d. Bet. 1871 - 1964
12
Susan Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.7]
b. 1873 d. Between 1873 - 1966
12
C. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.8]
b. 1877 d. Between 1877 - 1878
12
Marcus Sylvester Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.9]
b. 8 May 1877 d. 12 Apr 1965 [
=>
]
12
Elijah W. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.1.10]
b. Jul 1879 d. Between 1896 - 1969 [
=>
]
11
Nathaniel Jackson King, I
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2]
b. 1841 d. 14 Dec 1862
Hettie Gibson
b. 1844 d. 21 Oct 1904
12
Nathaniel Jackson King, II
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.2.1]
b. 16 Dec 1862 d. 25 Feb 1931 [
=>
]
11
William Nathan King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.3]
b. 1843 d. Bet. 1843 - 1946
11
Elizabeth King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4]
b. 1845 d. 18 Feb 1927
James Dickson
b. 1828 d. 1901
12
Mary L. Dixon
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.1]
b. 1862 d. Aft 1880
12
Elizabeth Jane Dixon
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.2]
b. 04 May 1864 d. 08 Jun 1940 [
=>
]
12
John Dixon
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.3]
b. 1866 d. 02 May 1952 [
=>
]
12
_____ Dickson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.4]
b. 1868 d. Bef 1878
12
Margaret C. Dixon
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.5]
b. Abt Feb 1870 [
=>
]
12
S. Dickson
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.6]
b. 1872
12
R. S. Dixon
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.7]
b. 1874
12
G. S. Dixon
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.8]
b. 1876
12
Sarah Dixon
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.9]
b. 1878 d. 08 Jan 1917
12
James Amos Dixon
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.4.10]
b. 17 Sep 1879 d. 20 Jul 1947 [
=>
]
11
John Alfred King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.5]
b. 1846 d. 12 Sep 1905
+
Mary Ann Headly
b. Aft 1842
11
Mary Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6]
b. Nov 1848 d. 17 Dec 1921
John Alexander Clabough
b. Jan 1842 d. Bet. 1874 - 1934
12
Sarah Jane Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.1]
b. Nov 1874 d. 18 May 1899 [
=>
]
12
James Newton Clabo
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.2]
b. 24 Nov 1874 d. 14 Jun 1961 [
=>
]
12
Eliza E. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.3]
b. Dec 1876 d. Between 1893 - 1973
12
Susan M. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.4]
b. May 1879
12
_____ Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.5]
b. 1881
12
Mary Alice Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.6]
b. 21 Sep 1883 d. 12 Apr 1912 [
=>
]
12
_____ Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.7]
b. 1886 d. Bet. 1886 - 1889
12
Laura M. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.8]
b. Mar 1886 d. Between 1899 - 1979
12
Louisa A. Clabaugh
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.9]
b. Jun 1888
12
Reverand Lewis Andrew Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.10]
b. 6 Jun 1888 d. 6 Jan 1965 [
=>
]
12
Nancy M. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.11]
b. Jan 1891 d. Between 1905 - 1985
12
Robert R. Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.12]
b. Jul 1893 d. Bet. 1894 - 1982
12
Susie Clabough
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.6.13]
b. 1895 d. Between 1895 - 1988
11
Andrew Jackson King, Jr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7]
b. Jan 1852 d. 1920
Jemima Roberts
b. 1843 d. 1882
12
Jemima Lucinda King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.1]
b. Jun 1869 d. Bet. 1912 - 1964 [
=>
]
12
Margaret E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.2]
b. 1871
12
Caroline C. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.3]
b. 1873
12
Sarah M. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.4]
b. 1875
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.5]
b. Abt 1877 d. Abt 1877
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.6]
b. Abt 1879 d. Abt 1879
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.7]
b. Abt 1881
Tempie Jane Henry
b. Jan 1855 d. Between 1897 - 1949
12
Rhoda E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.8]
b. Mar 1884
12
Iota Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.9]
b. 30 Jun 1886 [
=>
]
12
Nancy M. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.10]
b. Jun 1888
12
William J. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.11]
b. 13 Jan 1891 d. 1 Dec 1942
12
Lewis Thomas King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.12]
b. 13 Jan 1893 d. 18 Aug 1977 [
=>
]
12
Josie A. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.7.13]
b. May 1897 [
=>
]
11
Henry Newton King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8]
b. 18 Nov 1855 d. 07 Feb 1934
Rachel Caldonia Henry
b. 20 Oct 1857 d. 30 Mar 1919
12
Andrew Jackson King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8.1]
b. 05 Sep 1879 d. 24 Feb 1945
12
Jr. Henry Newton King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8.2]
b. 29 Jan 1882 d. 02 Feb 1939
12
William Thomas King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8.3]
b. 23 Jun 1884 d. 26 Oct 1958
12
Lydia M. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8.4]
b. Mar 1887
12
Milas G. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8.5]
b. Jan 1890
12
Wiley B. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8.6]
b. Sep 1893
12
George M. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8.7]
b. Mar 1895
12
Pinkney R. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.8.8]
b. Sep 1899
11
Malvina Leida King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.9]
b. 2 Mar 1858 d. 15 Dec 1920
+
_____ Patterson
b. Bet. 1841 - 1861 d. Bet. 1875 - 1947
11
Jasper Andrew King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10]
b. 28 May 1860 d. 06 Dec 1920
Celia Cordelia Dickson
b. 20 Oct 1864 d. 28 Apr 1940
12
Debbie Caldonia King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.1]
b. 09 Dec 1861 d. 04 Feb 1940 [
=>
]
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.2]
b. 1881 d. Bet. 1881 - 1900
12
William King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.3]
b. 1883 d. Bet. 1883 - 1884
12
John Russell King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.4]
b. 15 Jan 1885 d. 14 Mar 1947 [
=>
]
12
Martha Jane King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.5]
b. 30 Aug 1886 d. 23 Feb 1952 [
=>
]
12
George Louis King, Sr.
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.6]
b. 5 May 1888 d. 3 Jun 1967 [
=>
]
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.7]
b. Abt 1889 d. Bet. 1890 - 1983
12
Jettie E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.8]
b. 15 Aug 1891 d. 13 May 1985 [
=>
]
12
James Harrison King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.9]
b. 11 Jan 1893 d. Between 1893 and 1985
12
Sarah Malonia King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.10]
b. Bet. 1882 -1903 d. Bet. 1882 -1903
12
Laura Ellen King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.11]
b. 6 Jun 1904 d. 9 Jun 1992 [
=>
]
12
Alma Mae King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.10.12]
b. 25 Jun 1908 d. 8 Nov 1953 [
=>
]
11
Sarah Sally King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11]
b. 15 Jun 1863 d. 19 Nov 1941
Robert Floyd
12
_____ Floyd
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.11.1]
b. Aft 1874 [
=>
]
11
Pleasant George King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.12]
b. Aug 1867 d. Bet. 1901 - 1946
Sarahn R. _____
b. Apr 1875
12
_____ King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.12.1]
b. Abt 1892
12
Susan L. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.12.2]
b. Apr 1894
12
Cora L. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.12.3]
b. Nov 1896
12
Coy R. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.12.4]
b. Apr 1898
12
James E. King
[1.1.1.1.1.1.1.1.1.10.12.5]
b. Mar 1900